COLAS FRANCE
Informations légales
- Dénomination
- COLAS FRANCE
- SIRET du siège
- 329 338 883 04510
- SIREN
- 329338883
- N° TVA intracommunautaire
- FR75329338883
- Numéro RCS
- 329 338 883 R.C.S. Paris
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Paris, le 19 mars 1984
- Inscription au RNE
- INSCRITle 19 mars 1984
- Forme juridique
- 5710 — SAS
- Capital social
- 54 156 052 €
- Code NAF
- 4211Z
- Catégorie
- GE
Activité
- Code NAF / APE
- 4211Z
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Forme d’exercice
- Commerciale
Profil INPI
- Forme d'exercice
- Activité commerciale
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Effectif exact (INPI)
- 18 547 salariés
- Représentants actifs
- 7
- Clôture d'exercice
- 31 décembre
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 18 mars 2083
- Dernière mise à jour INPI
- 15 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Non diffusable
- Registres antérieurs
- RNCS RNM
Adresse
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA, 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
Département 75
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Observations du greffe67 observations
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION JEAN POIRIER FORME JURIDIQUE Société par actions simplifiée (Société à associé unique) SIEGE SOCIAL Route Départementale 396 Rond Point de l'Autoroute 10310 Ville-sous-la- Ferté RCS Troyes 380 647 545
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LIANTS DISTRIBUTION FORME JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL 6 avenue Charles Lindberg 33700 Mérignac RCS 343 808 192 RCS Bordeaux
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ENTRETIEN ROUTIER DU CENTRE OUEST FORME JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL Rue du Bois Bouquin 37110 Château-Renault RCS 340 167 691 RCS Tours
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION RENOROUTE FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL Les Carrières RN76, 18000 Bourges RCS 393 827 373 RCS Bourges
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SMTP SADDIER MAURICE TRAVAUX FORME JURIDIQUE SASU SIEGE SOCIAL 217 rue des Celliers 74800 Saint Pierre en Faucigny RCS 308 196 245 RCS Annecy
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT COLAS NORD-EST, SAS, siège social : Immeuble Echnageur - 44 boulevard de la Mothe 54000 Nancy, 329 198 337 RCS Nancy
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, SASU, siège social : 2 rue Jean Mermoz 78114 Magny Les Hameaux, 329 168 157 RCS Versailles
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT COLAS SUD OUEST, SASU, Avenue Charles Lindbergh 33700 Merignac, 329 405 211 RCS Bordeaux
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, SASU, 2 avenue Tony Garnier Immeuble Echangeur 69007 Lyon, 329 393 797 RCS Lyon
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT COLAS MIDI MEDITERRANEE , SASU, siège social: 855 rue René Descartes 13100 Aix-En-Provence, 329 368 526 RCS AIX EN PROVENCE
Observations concernant l'établissement situé Z I Sud de la Nonne, BP 223 86100 Châtellerault : Fonds secondaire acquis par apport de la SA COLAS (552 025 314 RCS NANTERRE).
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 22 000 000.00 FRF nouveau montant : 3 353 878.38 EUR
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE BESLAND FRERES 352 602 957 RCS POITIERS A COMPTER DU 31.3.09 ET EFFE T RETROACTIF AU 01.01.2009
Fusion-absorption de la société TRAVAUX PUBLICS BO URGEOIS PICHARD SAS, dont le siège est à MINIHY-TR EGUIER (22220), Zone Artisanale de Kerfolic, 307 3 21 919 RCS ST BRIEUC, à compter du 31/03/2009, ave c effet rétroactif au 01/01/2009.
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE YONNAISE DE TRAVAUX FORME JURIDIQUE SAS à associé unique SIEGE SOCIAL ZI de belle place Bld Joseph Cugnot 85000 LA ROCHE SUR YON RCS 546 650 458 LA ROCHE SUR YON - à compter du 31.12.2012
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT PARTIEL D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE(S) AYANT PARTICIPE(S) A L'APPORT : SCREG OUEST SA, 314 583 782 rcs NANTES et SACER ATLANTIQUE SA, 389 571 977 rcs Nantes ayant leur siège social à NANTES 44300 Imm.Echangeur ZAC de la Chantrerie 2 rue Gaspard Coriolis - approuvé par AGE du 29.3.2013.
A compter du 29/03/2013, Suite à l'apport partiel d'actif de la société SCREG OUEST, SA ayant son siège social 2 rue Gaspard Cariolis 44300 Nantes (314583782 RCS Nantes), la société est devenue propriétaire du fonds sis à Prat Ty Glaon 29550 Plomodiern, précédemment exploité en location-gérance.
A compter du 29/03/2013, Suite à l'apport partiel d'actif de la société SACER ATLANTIQUE, SA ayant son siège social 2 rue Gaspard Cariolis 44300 Nantes (389 571 977 Nantes), la société est devenue propriétaire du fonds sis 4 allée de l'Abbé Grégoire 29000 Quimper, précédemment exploité en location-gérance.
A compter du 29/03/2013, Suite à l'apport partiel d'actif de la société SCREG OUEST, SA ayant son siège social 2 rue Gaspard Cariolis 44300 Nantes (314583782 RCS Nantes), la société est devenue propriétaire du fonds sis 53 rue Guy Autret 29000 Quimper, précédemment exploité en location-gérance.
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ENROBES 44 FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 2 rue Gaspard Corolis Imm Echangeur ZAC de Chantrerie 44300 NANTES RCS NANTES 334.056.702.à compter du 31.10.2013. avec effet rétroactif au 01.01.2013.
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ARNAUD ENROBES FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL Route De Parthenay 85120 LA TARDIERE RCS 392.108.890. LA ROCHE SUR YON à compter du 31.10.2013 avec effet rétroactif au 01.01.2013.
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION POITOU-LIMOUSIN-CHARENTE-ENROBES FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 86430 MOUTERRE SUR BLOURDE RCS POITIERS 328.581.996 à compter du 31.10.2013. avec effet rétroactif au 01.01.2013.
A compter du 22/11/2013 transfert de l'établissement secondaire de la rue René Réaumur au 9 rue Alfred Kastler ZI de Brais 44600 Saint-Nazaire
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LA TECHNOLOGIE ROUTIERE FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 7 BIS RUE DE BELLE ILE 72190 COULAINES RCS 351 009 709 RCS LE MANS - LE 31/12/2013 - Avec effet rétroactif au 01/01/2013
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LIANTS ROUTIERS BRETON FORME JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL Zone Industrielle de Gourhel 56800 PLOERMEL RCS VANNES n° 319 473 203, à compter du 08/04/2014 avec effet rétroactif au 01/01/2014
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION HELARY TRAVAUX PUBLICS FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL lieudit Roglazou 22970 PLOUMAGOAR RCS 428 716 146 RCS SAINT BRIEUC - approuvée lors de l'AGE du 31.12.2012 avec effet rétroactif au 01.01.2012
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION BRULE-WEICKERT TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENTS - TRANSPORTS FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL MINE BOUAR 56770 PLOURAY RCS 329 048 227 RCS LORIENT - LE 31/12/2013
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ENROBES 56 FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL ZA DE POULVERN 56550 LOCOAL-MENDON RCS 382 362 770 RCS LORIENT - le 31.10.2013 - Avec effet rétro-actif au 01.01.2013
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION VENDEE ENROBES FORME JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL ZI des Ajoncs 85000 LA ROCHE SUR YON RCS 409.596.897 RCS LA ROCHE SUR YON le 09.04.2015 avec effet rétroactif au 01.01.2015
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE DES ENROBES DE CORNOUAILLE FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 11 route de Penfrat 29000 QUIMPER RCS 350.819.215 RCS QUIMPER le 31.10.2013 avec effet rétroactif au 01.01.2013
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ILLE ET RANCE ENROBES FORME JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL 2 rue Gaspard Coriolis 44300 NANTES RCS 305.256.687 RCS NANTES le 09.4.2015 avec effet rétroactif au 01.01.2015
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION TEXROD FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL ROUTE DE DUN - LIEUDIT LES CARRIERES 18000 BOUGES RCS 312681075 RCS BOURGES - A COMPTER DU 31/12/2013
Transformation de la société Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Notification intergreffe reçue du GTC de Nantes le 23/07/2015
Fusion - L236-1 à compter du 01/01/2015 : Société absorbée ENROBES 72, Société en nom collectif (SNC), route de Paris 72470 CHAMPAGNE (RCS LE MANS (7202) 308 886 126)
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ENROBES 72 FORME JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL Route de Paris 72470 CHAMPAGNE RCS 308886126 RCS LE MANS
La société est réduite à un associé unique à compter du 01/12/2018 (Notification intergreffe reçue du GTC de NANTES le 01.03.2019)
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
Ouverture d'un nouvel établissement complémentaire situé : Chemin De la Granelle RN 86 30320 MARGUERITTES à compter du 01/08/2020
Ouverture d'un nouvel établissement complémentaire situé : 337 Chemin des Jonchères EADAC des Berthilliers 71850 CHARNAY-LES-MACON à compter du 01/08/2020
Etablissement sise 21 Rue de Dole 39410 SAINT-AUBIN : en application de l'article R.123-96 du Code de Commerce, l'activité de livraison de matériaux enrobés. est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au greffe dans les 15 jours de sa délivrance par l'autorité compétente. En cas de non respect de ce délai par l'assujetti, le greffier appliquera le 2ème alinéa de l'article R.123-100 du Code de Commerce
Ouverture de l'établissement complémentaire situé Lieu Dit Ron de Los Fados 48200 Rimeize à compter du 01/08/2020
Ouverture de l'établissement complémentaire situé Gardes 48000 Mende à compter du 01/08/2020
Ouverture de l'établissement complémentaire situé ZA du Causse d'Auge 48000 Mende à compter du 01/08/2020
Ouverture de l'établissement secondaire situé route d'Aubrac - Aumont-Aubrac 48130 Peyre en Aubrac à compter du 01/08/2020
Ouverture de l'établissement complémentaire situé le Bruel 48230 Esclanèdes à compter du 01/08/2020
Etablissement sis à VANNES, Rue Dutenos Le Verger - Modification de l'enseigne à compter du 01/08/2020 : Ancienne : Agence COLAS Vannes Nouvelle : Etablissement de Vannes
Etablissement sis à PLOERMEL, Rue Bernard Perrot - ZA du Bois Vert - Modification de l'enseigne à compter du 01/08/2020 Ancienne : Usine de Ploërmel Nouvelle : Etablissement Industriel de Ploërmel
Etablissement sis à VANNES, Route de Saint Léonard - ZI du Prat - Adoption d'une enseigne à compter du 01/08/2020 : Nouvelle enseigne : Etablissement Industriel de Vannes
Etablissement sis à PLOERMEL, ZA du Bois Vert - Adoption d'une enseigne à compter du 01/08/2020 : Etablissement Industriel de Ploërmel
Etablissement sis à PLOERMEL, Rue Bernard Perrot - Adoption d'une enseigne à compter du 01/08/2020 : Etablissement de Ploërmel
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
Transfert du siège social de "2, rue Gaspard Coriolis 44300 NANTES" au "1, rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS", à compter du 01/01/2021.
Changement de dénomination. Ancienne dénomination : COLAS CENTRE OUEST nouvelle dénomination Colas France, à compter du 01/01/2021
Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions à compter du 31/12/2020. Société(s) ayant participé à l'opération : COLAS NORD EST, SAS, 44 Boulevard de la Mothe -Immeuble échangeur 54000 NANCY (RCS NANCY 329198337) (société apporteuse) Les établissement sis: 122 rue Edouard Vaillant 62230 OUTREAU Ecluse St Bertin 62500 ST OMER 15 Rue René Cassin 62230 OUTREAU Rue de la Houlette- Zal de la Houlette 62240 DESVRES ont été préalablement immatriculés avec pour origine de fonds une création' à la date du 01/08/2020
Apport partiel d'actif à compter du 31/12/2020 d'un fonds sis ZA de l'angle Chamberet 19370 Chamberet Précédent propriétaire: COLAS SUD OUEST (329 405 211)
Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions à compter du 31.12.2020. Société(s) ayant participé à l'opération : COLAS SUD OUEST, Société par actions simplifiée à associé unique, Avenue Charles Lindbergh 33700 Mérignac (RCS Bordeaux 329 405 211)
Apport partiel d'actifs à compter du 31/12/2020 d'un fonds sis le pont de Molières La chapelle aux Brocs 19360 Malemort Précédent propriétaire: COLAS SUD-OUEST (329 405 211)
concerne le fonds sis les carrières - route nationale 76 - 18000 Bourges A compter du 01/05/2022 modification de l'origine du fonds suite à fusion absorption de RENOROUTE RCS BOURGES 393 827 373
Opération de fusion à compter du 01/05/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : RENOROUTE, Société à responsabilité limitée, les Carrières-Route Nationale 76 18000 Bourges (RCS Bourges 393 827 373)
Radiation du RCS de Castres le 31/08/2022
Radiation du RCS de Nice le 01/08/2020
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION BERRY ENVIRONNEMENT RECYCLAGE FORME JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL Route Départementale 2076 les Carrières-Bâtiment A 18000 Bourges RCS Bourges 441 911 047
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION NICOL ENVIRONNEMENT FORME JURIDIQUE SASU SIEGE SOCIAL Rue des Mottes 22440 Ploufragan RCS Saint Brieuc 433 946 381
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 22 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 353 878.38 EUR
Société immatriculée au tribunal de commerce de NANTES sous le numéro 1984B165.
Cycle de vie
- Création
- 19 mars 1984
- Immatriculation RCS
- 19 mars 1984
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 18 mars 2083
- Dernière MAJ INPI
- 15 avril 2026
Historique des formalités INPI84 événements
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
+ 54 événements plus anciens non affichés
Dirigeants
7 dirigeants enregistrés — 5 personnes physiques, 2 personnes morales
Président
Directeur général
Directeur général
Directeur général
Directeur général
Établissements
50 établissements au total — 50 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ÉtablissementSiège329 338 883 03413 | - | - | - | Actif |
| REZE329 338 883 00070 | 42.11Z Génie civil | 26 Rue DU GENERAL LECLERC 44400 REZE | 1 janvier 1984 | Actif |
| Établissement329 338 883 00088 | - | - | - | Actif |
| CHAMPAGNE329 338 883 00096 | 42.11Z Génie civil | 5 Route DE PARIS 72470 CHAMPAGNE | 24 août 1984 | Actif |
| Établissement329 338 883 00146 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00153 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00161 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00195 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00229 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00245 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00401 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00427 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00435 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00443 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00484 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00500 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00542 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00567 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00575 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00617 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00625 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00633 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00658 | - | - | - | Actif |
| VANNES329 338 883 00666 | 42.11Z Génie civil | ZI DU PRAT Rue DUTENOS LE VERGER 56000 VANNES | 1 décembre 2012 | Actif |
| Établissement329 338 883 00674 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00682 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00690 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00716 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00732 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00773 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00849 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00856 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00906 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00963 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 00989 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01011 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01029 | - | - | - | Actif |
| PLOUMAGOAR329 338 883 01078 | 42.11Z Génie civil | 1 Rue DU PAVILLON BLEU 22970 PLOUMAGOAR | 1 janvier 2013 | Actif |
| Établissement329 338 883 01086 | - | - | - | Actif |
| AIRVAULT329 338 883 01110 | 23.99Z | 5 Rue DES SABLIERES 79600 AIRVAULT | 31 octobre 2013 | Actif |
| Établissement329 338 883 01136 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01144 | - | - | - | Actif |
| VANNES329 338 883 01151 | 23.99Z | ZI DU PRAT Rue ST LEONARD 56000 VANNES | 29 mars 2013 | Actif |
| Établissement329 338 883 01177 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01185 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01193 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01201 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01219 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01227 | - | - | - | Actif |
| Établissement329 338 883 01250 | - | - | - | Actif |
Cartographie de COLAS FRANCE
20 connexionsEntreprises liées via des mandats communs
Évolution
Indicateurs financiers
9 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | |||||||||
| Chiffre d'affaires (€) | 533,7 M € | 603,1 M € | 653,3 M € | 715,0 M € | 642,3 M € | 3964,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 571,7 M € | 644,0 M € | 695,2 M € | 753,1 M € | 697,0 M € | 2953,5 M € | 4592,6 M € | 4609,0 M € | 4732,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -6,3 M € | 648 K € | 4,0 M € | 19,2 M € | -3,5 M € | -105,2 M € | -146,4 M € | -56,6 M € | -101,8 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,5 M € | 12,3 M € | 15,9 M € | 19,2 M € | 12,4 M € | 92,6 M € | 82,7 M € | 122,4 M € | 142,3 M € |
| Résultat financier (€) | 1,1 M € | 543 K € | 1,2 M € | -2,8 M € | 1,3 M € | 23,7 M € | 49,9 M € | 51,8 M € | 73,5 M € |
| Résultat courant (€) | 6,8 M € | 12,8 M € | 17,1 M € | 16,4 M € | 13,8 M € | 116,2 M € | 132,5 M € | 174,2 M € | 215,9 M € |
| Résultat exceptionnel (€) | -554 K € | -180 K € | -185 K € | -384 K € | 288 K € | 2,4 M € | 1,4 M € | 13,2 M € | -2,2 M € |
| Résultat net (€) | 4,6 M € | 11,4 M € | 13,3 M € | 8,8 M € | 9,4 M € | 82,8 M € | 102,7 M € | 133,7 M € | 157,1 M € |
| Croissance | |||||||||
| Taux de croissance du CA (%) | - | 13,0 % | 8,3 % | 9,4 % | -10,2 % | 517,2 % | -100,0 % | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 107,1 % | 106,8 % | 106,4 % | 105,3 % | 108,5 % | 74,5 % | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1,2 % | 0,1 % | 0,6 % | 2,7 % | -0,5 % | -2,6 % | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 % | 2,0 % | 2,4 % | 2,7 % | 1,9 % | 2,3 % | - | - | - |
| Production & ventes | |||||||||
| CA France (€) | 533,7 M € | 603,1 M € | 653,3 M € | 715,0 M € | 642,3 M € | 3964,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
| CA Export (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Production stockée (€) | 18 K € | -77 K € | -27 K € | 110 K € | 119 K € | -575 K € | 83 K € | 298 K € | -133 K € |
| Production immobilisée (€) | 529 K € | 249 K € | 226 K € | 618 K € | 714 K € | 4,4 M € | 10,8 M € | 6,3 M € | 6,7 M € |
| Subventions d'exploitation (€) | 70 K € | 45 K € | 39 K € | 6 K € | - | 116 K € | 297 K € | 322 K € | 152 K € |
| Total produits d'exploitation (€) | 571,7 M € | 644,0 M € | 695,2 M € | 753,1 M € | 697,0 M € | 4353,6 M € | 4592,6 M € | 4609,0 M € | 4732,8 M € |
| Achats & sous-traitance | |||||||||
| Achats de marchandises (€) | - | 253,5 M € | 276,7 M € | 291,7 M € | 216,4 M € | - | 1573,8 M € | 1492,9 M € | 1489,7 M € |
| Variation stocks marchandises (€) | - | - | - | - | 246,3 M € | - | - | - | - |
| Achats matières premières (€) | - | - | - | - | - | 1400,1 M € | - | - | - |
| Variation stocks matières (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | 360,9 M € | 166,0 M € | 184,6 M € | 205,2 M € | - | 1513,9 M € | 1573,8 M € | 1589,4 M € | 1665,0 M € |
| Autres charges (€) | 3,5 M € | 667 K € | 634 K € | 484 K € | 1,7 M € | -26,0 M € | 6,4 M € | 8,5 M € | 10,1 M € |
| Total charges d'exploitation (€) | 569,3 M € | 634,0 M € | - | 733,9 M € | 684,6 M € | 4261,0 M € | 4509,9 M € | 4486,6 M € | 4614,3 M € |
| Provisions | |||||||||
| Dotations provisions immob. (€) | - | 16,2 M € | 14,5 M € | 20,9 M € | 243 K € | - | 123,1 M € | 108,2 M € | 115,0 M € |
| Dotations provisions actif circulant (€) | 993 K € | 650 K € | 1,2 M € | 1,8 M € | 433 K € | 4,0 M € | - | 5,4 M € | 4,8 M € |
| Dotations provisions risques (€) | 15,4 M € | - | - | - | 23,0 M € | 115,9 M € | - | 33,0 M € | 644 K € |
| Provisions pour risques (€) | 17,9 M € | 18,0 M € | 21,8 M € | 23,1 M € | 133,3 M € | 132,2 M € | 131,3 M € | 133,6 M € | 122,7 M € |
| Provisions pour charges (€) | 37,8 M € | 40,2 M € | 38,4 M € | 44,8 M € | 283,3 M € | 261,5 M € | 260,9 M € | 273,3 M € | 288,7 M € |
| Total provisions (€) | 55,7 M € | 58,2 M € | 60,2 M € | 67,9 M € | 416,6 M € | 393,8 M € | 392,2 M € | 406,9 M € | 411,4 M € |
| Résultats financiers & exceptionnels | |||||||||
| Total produits financiers (€) | 2,0 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 29,8 M € | 56,7 M € | 67,2 M € | 95,4 M € |
| Total charges financières (€) | 915 K € | 825 K € | 777 K € | 4,6 M € | 507 K € | 6,2 M € | 6,8 M € | 15,4 M € | 21,9 M € |
| Total produits exceptionnels (€) | 992 K € | 156 K € | 74 K € | 224 K € | 355 K € | 8,4 M € | 12,4 M € | 24,7 M € | 5,3 M € |
| Total charges exceptionnelles (€) | 1,5 M € | 337 K € | 260 K € | 608 K € | 68 K € | 6,0 M € | 11,0 M € | 11,5 M € | 7,6 M € |
| Participation des salariés (€) | - | - | - | -684 K € | 660 K € | 10,4 M € | 10,2 M € | -20,2 M € | -19,1 M € |
| Impôt sur les bénéfices (€) | 1,6 M € | -1,2 M € | -3,6 M € | -6,5 M € | 4,0 M € | 25,5 M € | 21,0 M € | 33,6 M € | -37,4 M € |
| Total produits (€) | 577,9 M € | 645,5 M € | 700,9 M € | 758,4 M € | 699,2 M € | 4391,8 M € | 4661,7 M € | 4700,9 M € | 4833,6 M € |
| Total charges (€) | 573,4 M € | 634,1 M € | 687,6 M € | 749,6 M € | 689,8 M € | 4309,0 M € | 4559,0 M € | 4567,2 M € | 4676,5 M € |
| Gestion BFR | |||||||||
| BFR (€) | 37,4 M € | 2,4 M € | 40,3 M € | 28,2 M € | 62,8 M € | 34,2 M € | 94,1 M € | -101,0 M € | -60,1 M € |
| Trésorerie nette (€) | - | 70,0 M € | 51,6 M € | - | 409,5 M € | - | 506,1 M € | 699,8 M € | 732,8 M € |
| Stocks (€) | - | - | 8,6 M € | 8,5 M € | 45,4 M € | 52,7 M € | 67,7 M € | 64,5 M € | 62,7 M € |
| Créances clients (€) | 11,3 M € | 25,1 M € | 20,8 M € | 9,9 M € | 323,8 M € | 353,1 M € | 381,2 M € | 909,7 M € | 866,8 M € |
| Disponibilités (€) | - | 70,0 M € | 51,6 M € | - | 409,5 M € | - | 506,1 M € | 699,8 M € | 732,8 M € |
| Autonomie financière | |||||||||
| Capitaux propres (€) | 53,4 M € | 64,8 M € | 78,1 M € | 83,5 M € | 535,0 M € | 593,5 M € | 584,5 M € | 604,8 M € | 620,8 M € |
| Dettes financières (€) | 69,3 M € | 58,1 M € | 67,8 M € | 161 K € | 222,5 M € | 246,7 M € | - | 172,8 M € | 173,7 M € |
| Autonomie financière (%) | 14,9 % | 16,5 % | 18,7 % | 19,3 % | 21,6 % | 23,1 % | 23,4 % | 22,9 % | 23,7 % |
| Solvabilité | |||||||||
| Total actif (€) | 358,9 M € | 392,0 M € | 417,0 M € | 433,8 M € | 2471,3 M € | 2569,0 M € | 2502,1 M € | 2641,7 M € | 2623,6 M € |
| Total dettes (€) | 249,7 M € | 269,0 M € | 278,7 M € | 282,3 M € | 1519,8 M € | 1581,7 M € | 1525,4 M € | 1630,0 M € | 1591,4 M € |
| Dettes fournisseurs (€) | 92,6 M € | 108,8 M € | 105,8 M € | 103,0 M € | 599,0 M € | 617,5 M € | 618,7 M € | 675,5 M € | 624,7 M € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 49,1 M € | 55,3 M € | 56,9 M € | 61,5 M € | 384,9 M € | 378,9 M € | 410,0 M € | 452,0 M € | 456,0 M € |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette (%) | 0,9 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,1 % | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | 8,6 % | 17,6 % | 17,0 % | 10,5 % | 1,8 % | 13,9 % | 17,6 % | 22,1 % | 25,3 % |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | 0,7 % | 3,1 % | 3,8 % | 4,4 % | 0,5 % | 3,6 % | 3,3 % | 4,6 % | 5,4 % |
| Valeur ajoutée (€) | 210,8 M € | 478,0 M € | 510,6 M € | 547,9 M € | 697,0 M € | 1439,7 M € | 3018,8 M € | 3019,6 M € | 3067,8 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,5 % | 79,3 % | 78,2 % | 76,6 % | 108,5 % | 36,3 % | - | - | - |
| Bilan actif détaillé | |||||||||
| Actif immobilisé (€) | 116,9 M € | 119,2 M € | 124,1 M € | 121,2 M € | 741,7 M € | 709,9 M € | 659,0 M € | 644,0 M € | 664,2 M € |
| Actif circulant (€) | 242,0 M € | 272,8 M € | 292,9 M € | 312,6 M € | 1729,6 M € | 1859,1 M € | 1843,1 M € | 1997,7 M € | 1959,4 M € |
| Autres créances (€) | 154,6 M € | 156,6 M € | 201,6 M € | 211,1 M € | 890,0 M € | 804,4 M € | 830,7 M € | 263,3 M € | 234,9 M € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | - | - | - | 74,3 M € | - | 592,6 M € | - | - | - |
| Charges constatées d'avance (€) | 13,2 M € | 13,1 M € | - | - | - | 56,4 M € | 57,4 M € | - | 62,3 M € |
| Bilan passif détaillé | |||||||||
| Capital social (€) | 7,4 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 54,1 M € | 54,1 M € | 54,1 M € | 54,1 M € | 54,1 M € |
| Primes d'émission / fusion (€) | 16,3 M € | 16,3 M € | 16,3 M € | 16,3 M € | 396,0 M € | 396,0 M € | 396,0 M € | 396,0 M € | 386,3 M € |
| Réserves légales (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres réserves (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Report à nouveau (€) | 24,7 M € | 29,3 M € | 40,7 M € | 50,7 M € | 51,8 M € | 38,8 M € | 11,7 M € | 1,2 M € | 0 € |
| Résultat de l'exercice (€) | 4,6 M € | 11,4 M € | 13,3 M € | 8,8 M € | 9,4 M € | 82,8 M € | 102,7 M € | 133,7 M € | 157,1 M € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | 5,3 M € | 10,3 M € | 7,9 M € | 5,0 M € | 5,7 M € | 10,0 M € | 20,3 M € | 8,8 M € | 6,5 M € |
| Autres dettes (€) | - | 28,3 M € | 28,0 M € | 36,8 M € | 212,6 M € | 201,4 M € | 214,1 M € | 211,0 M € | 204,5 M € |
| Produits constatés d'avance (€) | - | - | - | - | - | 34,6 M € | - | - | 1,5 M € |
| Total passif (€) | 358,9 M € | 392,0 M € | 417,0 M € | 433,8 M € | 2471,3 M € | 2569,0 M € | 2502,1 M € | 2641,7 M € | 2623,6 M € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | |||||||||
| Salaires et traitements (€) | - | - | - | 193,5 M € | - | 1141,3 M € | - | - | 1244,8 M € |
| Charges sociales (€) | - | 176,7 M € | 182,7 M € | - | 173,4 M € | - | 1161,0 M € | 1225,4 M € | - |
| Impôts et taxes (€) | 7,6 M € | 8,0 M € | 8,6 M € | 9,0 M € | 8,7 M € | 44,1 M € | 47,5 M € | 41,5 M € | 44,1 M € |
| Dotations aux amortissements (€) | 12,2 M € | 12,2 M € | 14,0 M € | 14,6 M € | 14,3 M € | 67,8 M € | 57,4 M € | 48,3 M € | 40,2 M € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
COLAS FRANCE
75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
COLAS FRANCE
75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
COLAS FRANCE
75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
COLAS FRANCE
75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
COLAS FRANCE
75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
MOZERR SIGNAL
75008 Paris
COLAS FRANCE
75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT
IPF 69
75015 Paris 15e Arrondissement
IPF 69
75015 Paris 15e Arrondissement
IPF 69
75015 Paris 15e Arrondissement
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par COLAS FRANCE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT)
Mutations
30
Valeur cumulée
59 958 410 €
Surface cumulée
928 m²
Prix moyen / m²
64 610 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | Appartement Vente | 28 RUE CASTAGNARY | 39 m² | 2 | 345 000 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 133 RUE DE JAVEL | - | 0 | 350 000 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 118 RUE LECOURBE | - | 0 | 130 000 € |
| 30 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 175 RUE DE LA CONVENTION | 83 m² | 0 | 407 500 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 103 AV FELIX FAURE | - | 0 | 446 950 € |
| 30 juin 2025 | Appartement Vente | 133 RUE DE JAVEL | 42 m² | 2 | 350 000 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 11 B RUE TIPHAINE | - | 0 | 135 000 € |
| 30 juin 2025 | Appartement Vente | 15 RUE EMMANUEL CHAUVIERE | 21 m² | 1 | 197 400 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 118 RUE LECOURBE | - | 0 | 130 000 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 109 AV FELIX FAURE | - | 0 | 446 950 € |
| 30 juin 2025 | Appartement Vente | 11 RUE THEODORE DECK | 35 m² | 3 | 361 160 € |
| 30 juin 2025 | Appartement Vente | 109 AV FELIX FAURE | 47 m² | 2 | 446 950 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 28 RUE CASTAGNARY | - | 0 | 345 000 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 11 RUE THEODORE DECK | - | 0 | 361 160 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 28 RUE CASTAGNARY | - | 0 | 345 000 € |
| 30 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 11 B RUE TIPHAINE | 28 m² | 0 | 182 000 € |
| 27 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 68 RUE DU COMMERCE | 540 m² | 0 | 3 720 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 30 RUE VAUGELAS | - | 0 | 450 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Appartement Vente | 30 RUE VAUGELAS | 43 m² | 2 | 450 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 7 RUE FIZEAU | - | - | 4 992 334 € |
| 27 juin 2025 | Appartement Vente | 1 RUE JACQUES MAWAS | 50 m² | 3 | 435 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Modifications diversesbodaccModifications diverses — Colas France
- Ventes et cessionsbodaccVentes et cessions — Colas France, SPAC
{"descriptif": "Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : SPAC Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : Batiment A, 145 rue des Caboeufs 92230 Gennevilliers Capital : 5100000.00 EUR Numéro unique d'identification : 542064175 Lieu d'immatriculation : Nanterre. Société bénéficiaire de la scission : Colas France Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris Capital : 54134933.00 EUR Numéro
- Ventes et cessionsbodaccVentes et cessions — Colas France, SPAC
{"descriptif": "Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : SPAC Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : Batiment A, 145 rue des Caboeufs 92230 Gennevilliers Capital : 5100000.00 EUR Numéro unique d'identification : 542064175 Lieu d'immatriculation : Nanterre. Société bénéficiaire de la scission : Colas France Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris Capital : 54134933.00 EUR Numéro
- Ventes et cessionsbodaccVentes et cessions — Colas France, CARRIERES & MATERIAUX NORMANDIE
{"descriptif": "Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Colas France Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris Capital : 54134933.00 EUR Numéro unique d'identification : 329338883 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : CARRIERES & MATERIAUX NORMANDIE Forme : Société en nom collectif Adresse du siège : 2 rue Jean Mermoz 78114 Magny-Les-Hameaux Capital : 40000.00 EUR Numéro unique d'id
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Vie sociale & négociation collective
Dernier accord signé le20 accords publiés sur Legifrance depuis 2017.
Source : dataset ACCO de la DILA. Mis à jour chaque semaine.
Accords récents
AVENANT 2 A L ACCORD VALANT STATUT COLLECTIF
Negociation annuelle
ACCORD DE NAO
accord sur le fonctionnement des CSE et CSE C
accord d'harmonisation
accord d'harmonisation
accord sur le périmètre des élections professionnelles
accord d'alignement des dates d'élections
avenant de specialité transport
composition du CSE CENTRAL ET COLONIES
Avenant n°5 relatif aux temps de travail exceptionnels des salariés des établissements de l'activité Génie Civil du territoire Ile-de-France Normandie - Avenant de spécialité Génie Civil
accord relatif à la négociation annuelle obligatoire
avenant à l'accord portant statut collectif
protocole d'accord d'harmonisation
ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELS DES ETABLISSEMENTS DE LA DIRECTION D'ACTIVITE GENIE CIVIL DU TERRITOIRE ILE-DE-FRANCE NORMANDIE
accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France
Protocole d'accord du 29 octobre 2020 en vue de la mise en place d'un statut social harmonisé des salariés de la Société COLAS FRANCE au 1er janvier 2021
Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
Un Accord Complémentaire visant au Déploiement de l'Accord de Référence du Groupe COLAS portant sur la Mixité & l'Egalité Professionnelle, au sein de COLAS CENTRE OUEST
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE d'Etablissements & du CSE Central
Données mises à jour le 13 avril 2026
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.